Skip to main content

Box 67

 Container

Contains 52 Results:

Le Rahier

 unspecified — Box: 67, Folder: 31
Scope and Contents
  1. ALS to General Lafayette
  2. 23 Novembre 1823, 2 ll.
Dates: 1520-1973.

Le Ray de Chaumont, James Donatien, 1760-1840

 unspecified — Box: 67, Folder: 32
Scope and Contents
  1. ALS to General Lafayette
  2. 3 April 1818, New York. 1l.
Dates: 1520-1973.

Le Ray de Chaumont, James Donatien, 1760-1840

 unspecified — Box: 67, Folder: 33
Scope and Contents
  1. ALS to General Lafayette
  2. 1st May 1825, New York. 1l.
Dates: 1520-1973.

Le Ray de Chaumont, James Donatien, 1760-1840

 unspecified — Box: 67, Folder: 34
Scope and Contents
  1. ALS to General Lafayette
  2. 23 Avril 1829, LeRaysville. 1l.
Dates: 1520-1973.

Le Ray de Chaumont, James Donatien, 1760-1840

 unspecified — Box: 67, Folder: 35
Scope and Contents
  1. ALS to General Lafayette
  2. 30 Septembre 1829, New York. 1l.
Dates: 1520-1973.

Le Ray de Chaumont, James Donatien, 1760-1840

 unspecified — Box: 67, Folder: 36
Scope and Contents
  1. ALS to General [Lafayette]
  2. 6 Mars 1832, Albany. 1l.
Dates: 1520-1973.

La Rivière, comte de

 unspecified — Box: 67, Folder: 37
Scope and Contents
  1. ALS
  2. 22 Juillet 1747, 1l.
  3. Je suis bien fâché, monsieur...
Dates: 1520-1973.

La Rivière, comte de

 unspecified — Box: 67, Folder: 38
Scope and Contents
  1. ALS to M. le Marquis de Lafayette
  2. 10 Septembre 1763, 1l.
Dates: 1520-1973.

La Rivière, comte de

 unspecified — Box: 67, Folder: 39
Scope and Contents
  1. ALS to M. le Marquis de Lafayette
  2. 7 Janvier 1766, 1l.
Dates: 1520-1973.

La Rivière, comte de

 unspecified — Box: 67, Folder: 40
Scope and Contents
  1. LS [aman.] to Mlle. de Lafayette
  2. 19 Mars 1773, Paris. 1l.
Dates: 1520-1973.